Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Montgomery County (Alabama)

Wikimedia-Liste

Die Liste der Registered Historic Places im Montgomery County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im Montgomery County in Alabama auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.

Aktuelle Einträge Bearbeiten

Lfd. Nr. Name Bild Datum der Eintragung Adresse/Lage Ort ID-Nr. Beschreibung
1 Alabama State Capitol   15. Okt. 1966 Goat Hill, Ostende der Dexter Ave. Montgomery 66000152 Hat außerdem den Status eines National Historic Landmarks[1]
2 Alabama State University Historic District   8. Okt. 1998 915 S. Jackson St. Montgomery 98001228
3 Bell Building   15. Dez. 1981 207 Montgomery St. Montgomery 81000132
4 Brame House 17. Sep. 1980 402–404 S. Hull St. Montgomery 80000728
5 Building 800-Austin Hall   2. März 1988 Second St., Maxwell AFB Montgomery 87002178
6 Building 836-Community College of the Air Force Building   2. März 1988 Maxwell Blvd., Maxwell AFB Montgomery 87002182
7 Cassimus House   13. Aug. 1976 110 N. Jackson St. Montgomery 76000349
8 City of St. Jude Historic District   18. Juni 1990 2048 W. Fairview Ave. Montgomery 90000916
9 Cleveland Court Apartments 620-638   29. Okt. 2001 620-638 Cleveland Ct. Montgomery 01001167
10 Cloverdale Historic District   12. Sep. 1985 grob begrenzt durch Norman Bridge und Cloverdale Rd., Fairview Ave. und Felder Av. sowie Boultier St. Montgomery 85002161
11 Cottage Hill Historic District   7. Nov. 1976 grob begrenzt durch Goldthwaite, Bell, Holt und Clayton St. Montgomery 76000350
12 Court Square Historic District   1. März 1982 21-35 Court St., 1-2 Dexter Ave., 18-24 N. Court St. und Court Sq. Montgomery 82002062
13 Court Square-Dexter Avenue Historic District (Boundary Increase) 30. Aug. 1984 grob entlang Dexter Ave., Perry, Court und Monroe St. Montgomery 84000697
14 Dexter Avenue Baptist Church   1. Juli 1974 454 Dexter Ave. Montgomery 74000431 Hat außerdem den Status eines National Historic Landmarks[2]
15 Dexter Avenue Baptist Church 10. März 1982 309 S. Jackson St. Montgomery 82002064
16 Dowe Historic District   29. Dez. 1988 320 und 334 Washington Ave. sowie 114-116 S. Hull St. Montgomery 88003076
17 Dr. C. A. Thigpen House   13. Dez. 1977 1412 S. Perry St. Montgomery 77000215
18 Edgewood   24. Apr. 1973 3175 Thomas Ave. Montgomery 73000367
19 First White House of the Confederacy   25. Juni 1974 644 Washington Ave. Montgomery 74000432
20 Garden District   13. Sep. 1984 grob begrenzt von Norman Bridge Rd., Court St., Jeff Davis Ave. und Fairview Aves. Montgomery 84000698
21 Gay House   15. März 1975 230 Noble Ave. Montgomery 75000325
22 Gerald-Dowdell House   28. Apr. 1980 405 S. Hull St. Montgomery 80000729
23 Gov. Thomas G. Jones House 8. Dez. 1978 323 Adams Ave. Montgomery 78000506
24 Governor’s Mansion   3. Juli 1972 1142 S. Perry St. Montgomery 72000172
25 Grace Episcopal Church   19. Feb. 1982 Pike Rd. Mount Meigs 82002067
26 Harrington Archaeological Site 25. Jan. 1979 Adresse Verschlusssache Montgomery 79000394
27 Huntingdon College Campus Historic District   24. Feb. 2000 1500 E. Fairview Ave. Montgomery 00000138
28 Jefferson Davis Hotel   13. März 1979 Ecke Catoma St. und Montgomery Sts. Montgomery 75000324
29 Jefferson Franklin Jackson House   17. Mai 1984 409 S. Union St. Montgomery 84000711
30 Jere Shine Site 8. Dez. 1978 Adresse Verschlusssache Montgomery 78000507
31 Lower Commerce Street Historic District   25. Feb. 1982 grob begrenzt durch die Bahnstrecke, N. Court, Commerce, Coosa und Tallapoosa St. Montgomery 82002063
32 Maxwell Air Force Base Senior Officer’s Quarters Historic District   2. März 1988 West Dr., N. Juniper St. & S. Juniper St., Inner Circle, Center Dr., Sequoia Dr., East Dr. auf der Maxwell Air Force Base Montgomery 87002177
33 McBryde-Screws-Tyson House   28. Nov. 1980 433 Mildred St. Montgomery 80000730
34 Montgomery Greyhound Bus Station   16. Mai 2011 210 S. Court St. Montgomery 11000298
35 Montgomery Union Station and Trainshed   24. Juli 1973 Water St. Montgomery 73000368 Hat außerdem den Status eines National Historic Landmarks[3]
36 Mt. Zion AME Zion Church   4. Okt. 2002 467 Holt St. Montgomery 02001066
37 Muklassa 28. Aug. 1973 Adresse Verschlusssache Montgomery 73000369
38 Old Ship African Methodist Episcopal Zion Church   24. Jan. 1991 483 Holcombe St. Montgomery 90002177
39 Opp Cottage   4. Mai 1976 33 W. Jefferson Davis Ave. Montgomery 76000351
40 Ordeman-Shaw Historic District   13. Mai 1971 grob begrenzt durch McDonough, Decatur, Madison und Randolph St. Montgomery 71000105
41 Patrick Henry Brittan House   13. Dez. 1979 507 Columbus St. Montgomery 79000393
42 Pepperman House   1. März 1982 17 Mildred St. Montgomery 82002065
43 Perry Street Historic District   16. Dez. 1971 grob begrenzt durch McDonough St. im Osten, Sayre St. im Westen, Washington St. im Norden und Donaldson St. im Süden Montgomery 71000106
44 Powder Magazine   13. Apr. 1973 am Ende der Eugene St. Montgomery 73000370
45 Sayre Street School   19. Feb. 1982 506 Sayre St. Montgomery 82002066
46 Scott Street Firehouse   12. Feb. 1981 418 Scott St. Montgomery 81000133
47 Semple House   27. Sep. 1972 725 Monroe St. Montgomery 72000174
48 Shepherd Building   22. Mai 1986 312 Montgomery St. Montgomery 86001106
49 Smith-Joseph-Stratton House   11. Apr. 1985 302 Alabama St. Montgomery 85000736
50 South Perry Street Historic District   30. Aug. 1984 grob entlang der Perry St. zwischen Washington St. und Dexter Ave. Montgomery 84000713
51 St. John’s Episcopal Church   24. Feb. 1975 113 Madison Ave. Montgomery 75000326
52 Stay House   10. Sep. 1979 631 S. Hull St Montgomery 79000396
53 Steiner-Lobman and Teague Hardware Buildings   31. Jan. 1979 184 and 172 Commerce St. Montgomery 79000397
54 Stone Plantation   31. Dez. 2001 5001 Old Selma Rd. Montgomery 01001411
55 Tankersley Rosenwald School   22. Jan. 2009 Hope Hull 08001332
56 The Murphy House   24. März 1972 22 Bibb St. Montgomery 72000173
57 Tulane Building   21. März 1979 800 High St. Montgomery 79000398
58 Tyson-Maner House   10. Mai 1979 469 S. McDonough St. Montgomery 79000399
59 United States Post Office and Courthouse-Montgomery 3. Juni 1998 Church St. zwischen Moulton und Lee St. Montgomery 98000611 Hat außerdem den Status eines National Historic Landmarks[4]
60 Winter Building   14. Jan. 1972 2 Dexter Ave. Montgomery 72000175
61 Winter Place   31. Mai 2006 454 S. Goldwaite St. Montgomery 06000439
62 William Lowndes Yancey Law Office   7. Nov. 1973 Ecke Adams St. und Perry St. Montgomery 73000371

Siehe auch Bearbeiten

Weblinks Bearbeiten

Anmerkungen Bearbeiten

  1. Listing of National Historic Landmarks by State: Alabama. National Park Service, abgerufen am 5. April 2020.
  2. Listing of National Historic Landmarks by State: Alabama. National Park Service, abgerufen am 2. April 2020.
  3. Listing of National Historic Landmarks by State: Alabama. National Park Service, abgerufen am 2. April 2020.
  4. Listing of National Historic Landmarks by State: Alabama. National Park Service, abgerufen am 2. April 2020.