Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Multnomah County

Wikimedia-Liste

Liste der Einträge im National Register of Historic Places in Multnomah County, Oregon, außerhalb der Stadt Portland, in das National Register of Historic Places eingetragenen Gebäude, Bauwerke, Objekte, Stätten oder historischen Distrikte.

In der Stadt Portland Bearbeiten

Siehe:

Außerhalb Portland Bearbeiten

Auflistung Bearbeiten

[1] Name Bild Eintragsdatum Lage Ort Beschreibung
1 Emanuel and Christina Anderson House
 
Emanuel and Christina Anderson House
22. Mai 2005
ID-Nr. 05000448
1420 SE Roberts Avenue
45° 29′ 10,8″ N, 122° 25′ 0,5″ W
Gresham
2 Rae Selling Berry Garden and House
 
Rae Selling Berry Garden and House

weitere Bilder
31. Dez. 2002
ID-Nr. 02001637
11505 SW Summerville Avenue
45° 26′ 32,6″ N, 122° 39′ 42,8″ W
Portland
3 Bonneville Dam Historic District
 
Bonneville Dam Historic District
9. Apr. 1986
ID-Nr. 86000727
zwischen Interstate 84 und Washington State Route 14
45° 38′ 29″ N, 121° 56′ 40,6″ W
Bonneville (und North Bonneville, Washington) Erbaut in den 1930, Dammbauwerk mit hydroelectrischen Kraftwerk, Leistung: 500.000 kW.
4 Bybee–Howell House
 
Bybee–Howell House

weitere Bilder
5. Nov. 1974
ID-Nr. 74001716
13901 NW Howell Park Road
45° 38′ 29″ N, 122° 49′ 7,9″ W
Sauvie Island
5 Columbia River Highway Historic District
 
Columbia River Highway Historic District

weitere Bilder
12. Dez. 1983
ID-Nr. 83004168
Straße entlang des Columbia River
45° 32′ 23,1″ N, 122° 14′ 38,8″ W
Troutdale bis The Dalles Erbaut zwischen 1913 and 1922, vor allem zur Förderung des Tourismus für den Columbia River Gorge
6 Elliott R. Corbett House
 
Elliott R. Corbett House
3. Okt. 1996
ID-Nr. 96001070
01600 SW Greenwood Road
45° 26′ 1,2″ N, 122° 39′ 43,5″ W
Portland (Umgebung) Erbaut 1915, Baustil: Colonial Revival, Wohnhaus nach dem Entwurf von Whitehouse and Fouilhoux[2]
7 H. L. and Gretchen Hoyt Corbett House
 
H. L. and Gretchen Hoyt Corbett House
28. Feb. 1991
ID-Nr. 91000129
01405 SW Corbett Hill Circle
45° 26′ 18,8″ N, 122° 39′ 50,4″ W
Portland
8 Maurice Crumpacker House
 
Maurice Crumpacker House

weitere Bilder
23. Okt. 1992
ID-Nr. 92001378
12714 SW Iron Mountain Boulevard
45° 25′ 58,9″ N, 122° 39′ 30,1″ W
Portland (Umgebung)
9 Fairview City Jail
 
Fairview City Jail
23. Mai 2016
ID-Nr. 16000290
120 1st Street
45° 32′ 21,8″ N, 122° 26′ 1,4″ W
Fairview
10 Roy and Leola Gangware House
 
Roy and Leola Gangware House
23. Feb. 1990
ID-Nr. 90000284
4848 SW Humphrey Boulevard
45° 30′ 16,5″ N, 122° 43′ 35,1″ W
Portland
11 William Gedamke House
 
William Gedamke House
13. Nov. 1989
ID-Nr. 89001970
1304 E Powell Boulevard
45° 29′ 51,6″ N, 122° 25′ 6,4″ W
Gresham Erbaut ca. 1900, Baustil Queen-Anne-Stil
12 Andreas Graf House
 
Andreas Graf House
13. Nov. 1980
ID-Nr. 80003356
44222 SE Loudon Road
45° 30′ 39,7″ N, 122° 12′ 29,3″ W
Corbett Erbaut 1985, Baustil ursprünglich Carpenter Gothic, 1891 umgestaltet zum Queen-Anne-Stil.
13 Gresham Carnegie Library
 
Gresham Carnegie Library

weitere Bilder
24. Jan. 2000
ID-Nr. 99001715
410 N Main Street
45° 30′ 1,9″ N, 122° 25′ 50,6″ W
Gresham
14 Charles Hunter Hamlin House
 
Charles Hunter Hamlin House
7. Juni 2016
ID-Nr. 16000346
1322 SE 282nd Avenue
45° 29′ 12,9″ N, 122° 22′ 20,3″ W
Gresham
15 Fred Harlow House
 
Fred Harlow House
16. Feb. 1984
ID-Nr. 84003078
726 E Historic Columbia River Highway
45° 32′ 17,3″ N, 122° 22′ 57,1″ W
Troutdale
16 Pierre Rossiter and Charlotte Hines House
 
Pierre Rossiter and Charlotte Hines House
20. Juni 2002
ID-Nr. 02000660
02393 SW Military Road
45° 26′ 33,7″ N, 122° 39′ 17,5″ W
Portland
17 Dr. Herbert H. Hughes House
 
Dr. Herbert H. Hughes House
5. Sep. 2001
ID-Nr. 01000932
1229 W Powell Boulevard
45° 29′ 50,7″ N, 122° 26′ 40,4″ W
Gresham
18 Joseph Jacobberger Country House
 
Joseph Jacobberger Country House

weitere Bilder
24. Jan. 2011
ID-Nr. 10001171
5545 SW Sweetbriar Street
45° 29′ 56″ N, 122° 44′ 4″ W
Portland Erbaut 1916, Architekt: Joseph Jacobberger (1869–1930)
19 C. Hunt and Gertrude McClintock Lewis House
 
C. Hunt and Gertrude McClintock Lewis House
3. März 2015
ID-Nr. 15000054
11645 SW Military Lane
45° 26′ 26,8″ N, 122° 39′ 12,3″ W
Portland
20 Louise Home Hospital and Residence Hall
 
Louise Home Hospital and Residence Hall
10. Sep. 1987
ID-Nr. 87001556
722 NE 162nd Avenue
45° 31′ 41,5″ N, 122° 29′ 44,6″ W
Gresham
21 Donald and Ruth McGraw House
 
Donald and Ruth McGraw House
3. Sep. 2001
ID-Nr. 01000935
01845 SW Military Road
45° 26′ 22,4″ N, 122° 39′ 35″ W
Portland
22 Multnomah County Poor Farm
 
Multnomah County Poor Farm

weitere Bilder
1. Juni 1990
ID-Nr. 90000844
2126 SW Halsey Street
45° 32′ 13,2″ N, 122° 24′ 24,4″ W
Troutdale
23 Multnomah Falls Lodge and Footpath
 
Multnomah Falls Lodge and Footpath

weitere Bilder
22. Apr. 1981
ID-Nr. 81000512
Historic Columbia River Highway, nordöstlich von Bridal Veil
45° 34′ 38,1″ N, 122° 7′ 2″ W
Bridal Veil (Umgebung)
24 E. J. O'Donnell House
 
E. J. O'Donnell House
28. Jan. 1994
ID-Nr. 93001564
5535 SW Hewett Boulevard
45° 30′ 16″ N, 122° 44′ 3,7″ W
Portland
25 Charles and Fae Olson House
 
Charles and Fae Olson House

weitere Bilder
7. Sep. 2007
ID-Nr. 07000921
765 SW Walters Road
45° 29′ 29,7″ N, 122° 26′ 1,6″ W
Gresham
26 David and Marianne Ott House
 
David and Marianne Ott House
20. Apr. 2015
ID-Nr. 15000167
2075 SE Palmblad Road
45° 28′ 56,8″ N, 122° 24′ 14,2″ W
Gresham
27 John V. G. Posey House
 
John V. G. Posey House
17. Okt. 1990
ID-Nr. 90001517
02107 SW Greenwood Road
45° 26′ 11,4″ N, 122° 39′ 26,4″ W
Portland
28 Dr. A. E. and Phila Jane Rockey House
 
Dr. A. E. and Phila Jane Rockey House

weitere Bilder
2. Dez. 1985
ID-Nr. 85003036
10263 SW Riverside Drive
45° 27′ 2,6″ N, 122° 39′ 37,4″ W
Portland
29 Percy A. Smith House
 
Percy A. Smith House
22. Feb. 1991
ID-Nr. 91000135
01837 SW Greenwood Road
45° 26′ 10,9″ N, 122° 39′ 37,6″ W
Portland
30 Stanley C. E. Smith House
 
Stanley C. E. Smith House
19. Juni 1991
ID-Nr. 91000796
01905 SW Greenwood Road
45° 26′ 11,2″ N, 122° 39′ 30,5″ W
Portland (Umgebung)
31 Springdale School
 
Springdale School

weitere Bilder
25. Okt. 2011
ID-Nr. 11000771
32405 E Historic Columbia River Highway
45° 31′ 9,8″ N, 122° 19′ 46,5″ W
Corbett (Umgebung)
32 Sunken Village Archeological Site (35MU4)
 
Sunken Village Archeological Site (35MU4)
20. Dez. 1989
ID-Nr. 89002455

Adresse nicht veröffentlicht
Sauvie Island Archäologische Stätte, einstmals ein Dorf der Chinookan
33 Troutdale Methodist Episcopal Church
 
Troutdale Methodist Episcopal Church
9. Sep. 1993
ID-Nr. 93000921
302 SE Harlow Street
45° 32′ 21″ N, 122° 23′ 10,2″ W
Troutdale
34 View Point Inn
 
View Point Inn

weitere Bilder
28. Feb. 1985
ID-Nr. 85000367
40301 NE Larch Mountain Road
45° 31′ 58,6″ N, 122° 14′ 54,5″ W
Corbett Architekt: Carl L. Linde
35 Vista House
 
Vista House

weitere Bilder
5. Nov. 1974
ID-Nr. 74001705
Historic Columbia River Highway
45° 32′ 22,5″ N, 122° 14′ 39,8″ W
Crown Point
36 Whidden–Kerr House and Garden
 
Whidden–Kerr House and Garden
13. Okt. 1988
ID-Nr. 88001039
11648 SW Military Lane
45° 26′ 29,2″ N, 122° 39′ 7,8″ W
Portland Erbaut 1901, Architekt: William M. Whidden, Baustil: Prairie School
37 Theodore B. Wilcox Country Estate
 
Theodore B. Wilcox Country Estate
19. Feb. 1993
ID-Nr. 93000019
3707 SW 52nd Place
45° 29′ 46,5″ N, 122° 43′ 46,3″ W
Portland
38 Jacob Zimmerman House
 
Jacob Zimmerman House
5. Juni 1986
ID-Nr. 86001226
17111 NE Sandy Boulevard
45° 32′ 55″ N, 122° 29′ 13,9″ W
Gresham

Siehe auch Bearbeiten

Weblinks Bearbeiten

Commons: National Register of Historic Places in Multnomah County, Oregon – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Quelle Bearbeiten

Einzelnachweise Bearbeiten

  1. Die Nummerierung in dieser Listenspalte ist an der vom National Park Service vorgelegten Reihenfolge der Einträge orientiert; die Farben unterscheiden verschiedene Schutzgebietstypen des Nationalparksystems mit landesweiter Bedeutung (z. B. National Historic Landmarks) von den sonstigen Einträgen im National Register of Historic Places.
  2. Tess, John M., February 26, 199, National Register of Historic Places Registration Form: Corbett, Elliott R., House.